-
TOTAL PERSONNEL SERVICES LIMITED - Avery House, 8 Avery Hill Road, New Eltham, London, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04821915
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Avery House
- 8 Avery Hill Road
- New Eltham
- London
- SE9 2BD Avery House, 8 Avery Hill Road, New Eltham, London, SE9 2BD UK
Management
- Geschäftsführung
- FINNERTY, Martin Joseph
- Prokuristen
- CHS BUILDING & ENGINEERING SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.07.2003
- Alter der Firma 2003-07-04 20 Jahre
- SIC/NACE
- 78109
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Martin Joseph Finnerty
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-04-30
- Letzte Einreichung: 2015-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-07-18
- Letzte Einreichung: 2017-07-04
-
TOTAL PERSONNEL SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- TOTAL PERSONNEL SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04821915. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.07.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78109" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Avery House erreicht werden.
Jetzt sichern TOTAL PERSONNEL SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Total Personnel Services Limited - Avery House, 8 Avery Hill Road, New Eltham, London, Grossbritannien
- 2003-07-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TOTAL PERSONNEL SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2020-09-07) - COCOMP
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-notice-compulsory (2017-07-04) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-13) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-07-15) - DISS40
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2017-11-11) - SOAS(A)
-
gazette-notice-voluntary (2017-10-24) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2017-10-17) - DS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2013-09-26) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-22) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2013-07-30) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-10) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-10-23) - DISS40
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-08) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2012-08-08) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-08-04) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-08-01) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2012-07-31) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2011-11-24) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-04-11) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-10-16) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-30) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-06) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-07-06) - CH04
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-04-14) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-08-14) - 363a
-
legacy (2009-08-04) - 363a
-
legacy (2009-08-03) - 288c
-
resolution (2009-05-22) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-05-20) - AA
-
legacy (2009-04-28) - 287
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-10) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2007-06-21) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-05-12) - 288b
-
legacy (2006-05-23) - 288b
-
legacy (2006-07-20) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-06-05) - AA
-
legacy (2006-05-23) - 288a
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-09-12) - 363a
-
legacy (2005-06-09) - 288b
-
legacy (2005-06-09) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-08-06) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
resolution (2003-08-18) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2003-07-04) - NEWINC