-
THE YANKEE TRAVELLER LIMITED - Union Suite The Union Building, 51 - 59 Rose Lane, Norwich, Norfolk, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04694641
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Union Suite The Union Building
- 51 - 59 Rose Lane
- Norwich
- Norfolk
- NR1 1BY
- England Union Suite The Union Building, 51 - 59 Rose Lane, Norwich, Norfolk, NR1 1BY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COKER, Simon Allan
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.03.2003
- Gelöscht am:
- 2020-11-17
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Allan Coker
- Miss Jessica Marie Coker
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-01-31
- Letzte Einreichung: 2017-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-12
-
THE YANKEE TRAVELLER LIMITED Firmenbeschreibung
- THE YANKEE TRAVELLER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04694641. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 12.03.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.03.2013.Die Firma kann schriftlich über Union Suite The Union Building erreicht werden.
Jetzt sichern THE YANKEE TRAVELLER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Yankee Traveller Limited - Union Suite The Union Building, 51 - 59 Rose Lane, Norwich, Norfolk, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE YANKEE TRAVELLER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-compulsory (2020-11-17) - GAZ2
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-04-02) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-05-14) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-12-13) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-07) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-01-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-05-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-01) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-12) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-22) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2013-09-19) - TM02
-
second-filing-of-form-with-form-type (2013-04-15) - RP04
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-08) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-03-14) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-22) - AR01
-
legacy (2012-02-15) - MG02
-
legacy (2012-01-17) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-13) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-30) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-06) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-17) - AA
-
legacy (2009-03-25) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-03-20) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-11-21) - AA
-
legacy (2007-03-13) - 363a
-
legacy (2007-03-12) - 288c
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-04-04) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-11-22) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-10-04) - AA
-
legacy (2005-04-07) - 287
-
legacy (2005-04-01) - 363a
keyboard_arrow_right 2004
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2004-10-04) - AA
-
legacy (2004-05-14) - 363a
-
legacy (2004-04-15) - 225
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-05-09) - 395
-
legacy (2003-04-18) - 88(2)R
-
legacy (2003-03-31) - 288a
-
legacy (2003-03-31) - 288b
-
incorporation-company (2003-03-12) - NEWINC