-
4471672 LIMITED - Highfield Court Tollgate, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04471672
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Highfield Court Tollgate
- Chandlers Ford
- Eastleigh
- Hampshire
- SO53 3TZ Highfield Court Tollgate, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 3TZ UK
Management
- Geschäftsführung
- DUNNE, Simon Jonathan
- PROCTOR, Anthony Philip
- Prokuristen
- DUNNE, Simon Jonathan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.06.2002
- Alter der Firma 2002-06-27 21 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- SHELLEY MANOR APARTMENTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-09-30
- Letzte Einreichung: 2012-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-27
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-07-11
- Letzte Einreichung:
-
4471672 LIMITED Firmenbeschreibung
- 4471672 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04471672. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.06.2002 registriert. 4471672 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SHELLEY MANOR APARTMENTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 27.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Highfield Court Tollgate erreicht werden.
Jetzt sichern 4471672 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 4471672 Limited - Highfield Court Tollgate, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire, Grossbritannien
- 2002-06-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 4471672 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-05-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-05-19) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-06-14) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2018-07-04) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-05-24) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-07-04) - 600
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-05-15) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-05-25) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-05-26) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-26) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2014-03-25) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2014-03-25) - 600
-
resolution (2014-03-25) - RESOLUTIONS
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2014-03-24) - RP04
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-08-28) - CH01
-
gazette-notice-compulsary (2013-01-08) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-02-12) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-02-13) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-10) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-29) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2012-05-04) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name (2012-04-25) - TM01
-
legacy (2012-01-17) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
certificate-change-of-name-company (2011-10-27) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-09-09) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-10-31) - AA
-
legacy (2009-05-16) - 288a
-
legacy (2009-07-03) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-small (2008-11-03) - AA
-
legacy (2008-07-16) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-small (2007-11-01) - AA
-
legacy (2007-07-11) - 363a
-
legacy (2007-01-06) - 395
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-21) - 395
-
accounts-with-accounts-type-small (2006-10-27) - AA
-
legacy (2006-07-24) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-small (2005-01-25) - AA
-
legacy (2005-02-04) - 287
-
accounts-with-accounts-type-small (2005-11-08) - AA
-
legacy (2005-09-13) - 363a
keyboard_arrow_right 2004
-
auditors-resignation-company (2004-08-16) - AUD
-
legacy (2004-07-14) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
accounts-with-accounts-type-full (2003-10-24) - AA
-
legacy (2003-08-10) - 363s
-
legacy (2003-01-21) - 287
-
legacy (2003-01-21) - 225
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-07-19) - 288a
-
legacy (2002-07-19) - 287
-
legacy (2002-07-19) - 288b
-
incorporation-company (2002-06-27) - NEWINC