-
BRAND & DELIVER PRODUCTIONS LTD - 76, New Cavendish Street, London, W1G 9TB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04452496
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 76
- New Cavendish Street
- London
- W1G 9TB 76, New Cavendish Street, London, W1G 9TB UK
Management
- Geschäftsführung
- GALLOP, Benjamin James
- GALLOP, Julie Kate
- Prokuristen
- GALLOP, Julie Kate
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.05.2002
- Gelöscht am:
- 2020-05-25
- SIC/NACE
- 93290
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- BRAND & DELIVER LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-03-31
- Letzte Einreichung: 2014-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-06-14
- Letzte Einreichung:
-
BRAND & DELIVER PRODUCTIONS LTD Firmenbeschreibung
- BRAND & DELIVER PRODUCTIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04452496. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 31.05.2002 registriert. BRAND & DELIVER PRODUCTIONS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BRAND & DELIVER LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93290" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 76 erreicht werden.
Jetzt sichern BRAND & DELIVER PRODUCTIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Brand & Deliver Productions Ltd - 76, New Cavendish Street, London, W1G 9TB, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRAND & DELIVER PRODUCTIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-05-25) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-02-25) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-06-05) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-05-30) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-05-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-06-29) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-12) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-05-11) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-05-11) - 600
-
resolution (2015-05-11) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-02) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-05-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-02) - AA
-
resolution (2013-01-29) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2013-01-29) - SH08
-
resolution (2013-12-12) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2013-12-12) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2013-12-20) - SH03
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-03) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2012-06-18) - AP01
-
legacy (2012-03-29) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-17) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-28) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-28) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-21) - 288c
-
legacy (2009-06-25) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-11-18) - AA
-
legacy (2009-04-07) - 395
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-09-08) - AA
-
legacy (2008-06-10) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-04-14) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-06-04) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-11-30) - AA
-
legacy (2006-11-08) - 288c
-
legacy (2006-08-10) - 363a
-
legacy (2006-08-10) - 288c
-
legacy (2006-07-19) - 287
-
resolution (2006-07-19) - RESOLUTIONS
-
legacy (2006-02-13) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-02-05) - AA
-
legacy (2006-01-17) - 288c
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-06-16) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-04-01) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-06-24) - 363a
-
legacy (2004-06-24) - 288c
keyboard_arrow_right 2003
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2003-09-24) - AA
-
legacy (2003-06-19) - 363a
-
legacy (2003-05-21) - 225
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-10-02) - 88(2)R
-
memorandum-articles (2002-07-17) - MEM/ARTS
-
legacy (2002-07-08) - 288b
-
legacy (2002-07-08) - 287
-
certificate-change-of-name-company (2002-06-27) - CERTNM
-
legacy (2002-06-25) - 288a
-
incorporation-company (2002-05-31) - NEWINC