-
MISKELL FLOORING LIMITED - Recovery House 15-17 Roebuck Road, Hainault Business Park, Ilford, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04375072
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Recovery House 15-17 Roebuck Road
- Hainault Business Park
- Ilford
- Essex
- IG6 3TU Recovery House 15-17 Roebuck Road, Hainault Business Park, Ilford, Essex, IG6 3TU UK
Management
- Geschäftsführung
- MISKELL, Mary Philomena
- MISKELL, Patrick Oliver
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.02.2002
- Gelöscht am:
- 2018-12-05
- SIC/NACE
- 43390
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-09-04
- Letzte Einreichung: 2015-12-04
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-03-01
- Letzte Einreichung:
-
MISKELL FLOORING LIMITED Firmenbeschreibung
- MISKELL FLOORING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04375072. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 15.02.2002 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43390" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Recovery House 15-17 Roebuck Road erreicht werden.
Jetzt sichern MISKELL FLOORING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Miskell Flooring Limited - Recovery House 15-17 Roebuck Road, Hainault Business Park, Ilford, Essex, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MISKELL FLOORING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2018
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2018-09-05) - LIQ13
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-01-06) - LIQ03
-
gazette-dissolved-liquidation (2018-12-05) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-01-12) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-28) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-18) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2015-12-17) - 4.70
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-12-17) - 600
-
resolution (2015-12-17) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-27) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-02-27) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-06) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-06-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-02-24) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2009-06-16) - AA
-
legacy (2009-04-30) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-06-18) - AA
-
legacy (2008-04-23) - 363s
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-03-01) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-11-29) - 288c
-
legacy (2006-10-13) - 287
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2006-10-12) - AA
-
legacy (2006-02-24) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-07-15) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2005-07-05) - AA
-
legacy (2005-03-01) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2004-08-19) - AA
-
legacy (2004-02-28) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-02-14) - 88(2)R
-
legacy (2003-02-14) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2003-08-05) - AA
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-09-26) - 88(2)R
-
legacy (2002-09-26) - 225
-
legacy (2002-09-26) - 287
-
legacy (2002-09-26) - 288a
-
legacy (2002-09-26) - 288b
-
legacy (2002-03-14) - 287
-
legacy (2002-02-26) - 288b
-
legacy (2002-02-26) - 288a
-
incorporation-company (2002-02-15) - NEWINC