-
PROPERTY PARTNERSHIPS DEVELOPMENT MANAGERS (UK) LIMITED - Causeway House, 1 Dane Street, Bishop's Stortford, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04294991
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Causeway House
- 1 Dane Street
- Bishop's Stortford
- Hertfordshire
- CM23 3BT Causeway House, 1 Dane Street, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM23 3BT UK
Management
- Geschäftsführung
- GOSLING, Thomas Lentell
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.09.2001
- Alter der Firma 2001-09-27 22 Jahre
- SIC/NACE
- 7487
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- POSSESSIO NO. 2 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2010-09-30
- Letzte Einreichung: 2008-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2009-09-27
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-10-11
- Letzte Einreichung:
-
PROPERTY PARTNERSHIPS DEVELOPMENT MANAGERS (UK) LIMITED Firmenbeschreibung
- PROPERTY PARTNERSHIPS DEVELOPMENT MANAGERS (UK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04294991. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.09.2001 registriert. PROPERTY PARTNERSHIPS DEVELOPMENT MANAGERS (UK) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen POSSESSIO NO. 2 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "7487" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2008 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 27.09.2009.Die Firma kann schriftlich über Causeway House erreicht werden.
Jetzt sichern PROPERTY PARTNERSHIPS DEVELOPMENT MANAGERS (UK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Property Partnerships Development Managers (Uk) Limited - Causeway House, 1 Dane Street, Bishop's Stortford, Hertfordshire, Grossbritannien
- 2001-09-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROPERTY PARTNERSHIPS DEVELOPMENT MANAGERS (UK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2023-10-03) - WU07
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-miscellaneous (2022-02-10) - LIQ MISC
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-miscellaneous (2021-11-04) - LIQ MISC
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2021-10-13) - WU04
-
liquidation-compulsory-removal-of-liquidator-by-court (2021-10-13) - WU14
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2021-09-03) - WU07
-
liquidation-compulsory-removal-of-liquidator-by-court (2021-12-20) - WU14
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2021-12-20) - WU04
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2020-11-10) - WU07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2019-09-30) - WU07
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2018-09-26) - WU07
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2017-12-29) - WU04
-
liquidation-compulsory-removal-of-liquidator-by-court (2017-12-29) - WU14
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2017-09-12) - WU07
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-miscellaneous (2016-08-11) - LIQ MISC
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-miscellaneous (2015-09-23) - LIQ MISC
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-08) - AD01
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2014-08-06) - 4.31
keyboard_arrow_right 2010
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2010-10-06) - COCOMP
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-05-26) - 288b
-
legacy (2009-05-26) - 363a
-
gazette-notice-compulsary (2009-05-19) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-12-22) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2009-05-27) - DISS40
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-10-31) - AA
-
legacy (2007-10-15) - 363s
-
legacy (2007-09-07) - 288b
-
certificate-change-of-name-company (2007-08-21) - CERTNM
-
legacy (2007-10-02) - 225
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-10-30) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2006-06-02) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2005-11-21) - AA
-
legacy (2005-10-24) - 363s
-
legacy (2005-05-19) - 363s
-
legacy (2005-05-09) - 288a
-
legacy (2005-04-01) - 288a
keyboard_arrow_right 2004
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2004-06-23) - AA
-
legacy (2004-07-02) - 395
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-07-22) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2003-07-24) - AA
-
legacy (2003-08-19) - 288a
-
legacy (2003-10-09) - 363s
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-11-20) - 363s
-
legacy (2002-06-26) - 287
-
legacy (2002-03-18) - 225
keyboard_arrow_right 2001
-
memorandum-articles (2001-10-12) - MEM/ARTS
-
incorporation-company (2001-09-27) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2001-10-08) - CERTNM
-
legacy (2001-12-19) - 288a
-
legacy (2001-12-19) - 287
-
legacy (2001-12-19) - 288b